USA
Kentucky
Letcher County (cont.)
Webb, Annis Lorraine  b. 1919, d. 2000
Webb, Benjamin Monroe  b. 1854
Webb, Benjamin P  b. 1855
Webb, Benjamin R  b. 1844, d. 1927
Webb, Callie  b. 1886, d. 1965
Webb, David L  b. circa 1852, d. 1909
Webb, David Wesley  b. 1859
Webb, Delmer  b. 1911, d. 1980
Webb, Edgar Delmo  b. 1913, d. 1941
Webb, Edward Lincoln  b. 1860, d. 1941
Webb, Edward T  b. circa 1834
Webb, Ellen Jewett  b. 1870, d. 1934
Webb, Enoch  b. 1810, d. 1881
Webb, Enoch  b. circa 1850, d. 1929
Webb, Henry M  b. 1836, d. 1927
Webb, Herbert W  b. 1911, d. 1978
Webb, James  b. circa 1752, d. 1833
Webb, Jane  b. circa 1857
Webb, Jason Lewis  b. 1820, d. 1903
Webb, Jewell Marie  b. 1923, d. 1996
Webb, Joe Nelson  b. 1851, d. 1943
Webb, John Anderson  b. 1875, d. 1947
Webb, John Harrison  b. 1890, d. 1960
Webb, John Henry  b. 1878, d. 1949
Webb, John Snodgrass  b. 1876, d. 1962
Webb, Lettishia  b. 1817, d. 1901
Webb, Letty  b. circa 1846
Webb, Letty  b. 1865, d. 1948
Webb, Louella Irene  b. 1923, d. 1997
Webb, Mary Jane  b. 1848
Webb, Mattie  b. 1870, d. 1948
Webb, Miles Linsay  b. 1893, d. 1980
Webb, Nancy  b. 1848, d. 1922
Webb, Nancy Ritter  b. circa 1856, d. 1935
Webb, Nelson R  b. 1853
Webb, Nelson Robinett  b. 1860, d. 1945
Webb, Polly Ellen  b. 1896, d. 1966
Webb, Purthia Jane  b. 1851, d. 1936
Webb, Purthiah Jane  b. 1876, d. 1957
Webb, Riley  b. 1843, d. 1915
Webb, Sabina  b. 1902, d. 1989
Webb, Sarah  b. 1823, d. 1910
Webb, Sarah Ann  b. 1848, d. 1889
Webb, Sarah Birdie  b. 1888, d. 1979
Webb, Sarah Jane  b. 1871
Webb, Violet Irene  b. 1915, d. 1955
Webb, Walter Raleigh  b. 1887, d. 1953
Webb, William O  b. circa 1862, d. 1874
Webb, William Wiley  b. 1827, d. 1915
Webb, Woodrow  b. 1918, d. 1993
Whitaker, Isaac D  b. 1852, d. 1888
Whittaker, Cynthia Ann  b. 1867, d. 1940
Williams, Coley  b. 1850, d. 1855
Williams, Elizabeth  b. 1854, d. 1908
Williams, Hiram  b. 1852, d. 1940
Williams, Isaac  b. circa 1824
Williams, John  b. 1854
Williams, Mattie  b. 1879, d. 1953
Williams, Nancy  b. 1855, d. 1918
Williams, Robert L  b. 1882, d. 1963
Williams, William Henderson  b. 1875, d. 1946
Lewis
Magisterial District 5
Francis, Margerene  b. 1842, d. 1908
Stamper, John Whitt Jr  b. 1838, d. 1907
Petersville
Stamper, John Whitt Jr  b. 1838, d. 1907
Vanceburg
Blakemore, Lucy Neville  b. 1764, d. 1862
Francis, Margerene  b. 1842, d. 1908
Stamper, John Whitt Jr  b. 1838, d. 1907
Lewis County
Blakemore, Lucy Neville  b. 1764, d. 1862
Branson, Louisa  b. 1848, d. 1901
Francis, Margerene  b. 1842, d. 1908
Stamper, William Riley  b. 1840, d. 1891
Lincoln
Waynesburg
Holbrook, Henna  b. 1881, d. 1965
Madison
Berea
Hogg, Edd Coolidge PhD  b. 1925, d. 1979
Minter, Mae  b. 1892, d. 1913
Tutt, Thomas Kelly Jr.  b. 1865, d. 1956
Glades
Calhoun, Harlan D  b. 1878, d. 1968
Calhoun, Ida  b. 1893, d. 1984
Calhoun, John Child  b. 1851, d. 1939
Calhoun, Luther Kash  b. 1887, d. 1954
Calhoun, Minnie  b. 1880, d. 1952
Calhoun, Robert Lee  b. 1884, d. 1968
Kash, Maranda  b. 1855, d. 1922
Million
Carpenter, America Ellen  b. 1869, d. 1948
Carpenter, Mary Belle  b. 1876, d. before 1932
Lyons, Ada  b. 1885, d. 1935
Lyons, George Maxey  b. 1863, d. 1919
Lyons, Greene Riley  b. 1886, d. 1965
Richmond
Culton, Reynolds Hogg  b. 1898, d. 1970
Culton, William Pryse  b. 1906, d. 1979
Valley View
Carpenter, America Ellen  b. 1869, d. 1948
Lyons, George Maxey  b. 1863, d. 1919
Lyons, Hazel  b. 1904, d. 1984
Madison County
Carpenter, John Elliot  b. 1872, d. 1945
Carpenter, Lillie  b. 1878, d. 1948
Clark, Frank Lutes  b. 1877, d. 1966
Hogg, Ida G  b. 1873, d. 1956
Taylor, John W  b. 1884, d. 1917
Thompson, Omega  b. 1897, d. 1984
Walters, Marilda  b. 1872, d. 1951
Magoffin
Craft, Campbell C  b. 1852, d. 1914
Bloomington
Craft, James  b. 1859, d. between 1920 and 1958
Burning Fork
Adams, Benjamin B  b. 1828, d. 1901
Adams, Esther  b. 1865, d. 1941
Adams, Lavina  b. 1860
Adams, Martha E  b. 1869, d. 1958
Adams, Nancy J  b. 1864
Adams, William Monroe  b. 1862, d. 1949
Adams, William Riley  b. 1867, d. 1945
Caudill, Nancy  b. circa 1834
Conley
Bailey, John Henry  b. 1888, d. 1978
Gifford
Caudill, Phoebe Ann  b. 1873, d. 1958
Craft, James  b. 1859, d. between 1920 and 1958
Ivyton
Adams, William Riley  b. 1867, d. 1945
Webb, Riley  b. 1843, d. 1915
Lickburg
Caudill, Phoebe Ann  b. 1873, d. 1958
Precinct 1
Adams, George  b. circa 1832
Caudill, Nancy  b. circa 1834
Salyersville
Adams, Benjamin Henry  b. 1884, d. 1973
Adams, Betsy M  b. 1898
Adams, Carrie F  b. 1892, d. 1962
Adams, Cenia Elizabeth  b. 1889, d. 1968
Adams, Esther  b. 1865, d. 1941
Adams, Ida W  b. 1887
Adams, John Henry  b. 1857, d. 1935
Adams, John Washington  b. 1858, d. 1946
Adams, Lavina Esther  b. 1900, d. 1931
Adams, Martha E  b. 1869, d. 1958
Adams, Mid  b. 1897, d. 1958
Adams, Townsel C  b. 1890, d. 1952
Adams, Wiley John  b. 1895, d. 1974
Adams, William Monroe  b. 1862, d. 1949
Adams, William Riley  b. 1867, d. 1945
Bailey, John Henry  b. 1888, d. 1978
Caudill, Benjamin  b. circa 1799, d. circa 1850
Cooper, Laura  b. 1872, d. 1925
Craft, Lula Belle  b. circa 1897
May, Carrie Lee  b. 1894, d. 1983
May, Mary Catherine  b. 1856, d. 1928
Patrick, Reuben  b. 1864, d. 1944
Rice, John F  b. 1865, d. 1934
Webb, Cornelia  b. 1867, d. 1951
Magoffin County
Adams, Benjamin B  b. 1828, d. 1901
Adams, Martha E  b. 1869, d. 1958
Adams, Mid  b. 1897, d. 1958
Adams, William Riley  b. 1867, d. 1945
Calhoun, Evans  b. 1827, d. 1907
Carpenter, Susie  b. 1890, d. 1967
Caudill, Phoebe Ann  b. 1873, d. 1958
Craft, James  b. 1859, d. between 1920 and 1958
Craft, Martha  b. 1875, d. 1963
Hunsaker, Miles Millard  b. 1896, d. 1974
Lee, Daniel Boone  b. 1902, d. 1957
May, Carrie Lee  b. 1894, d. 1983
Minter, Thomas C  b. 1884, d. 1945
Patrick, Reuben  b. 1864, d. 1944
Polly, Sena Minerva  b. 1835, d. 1876
Ward, Eveline  b. 1830, d. 1920
Magofin
Saylersville
Adams, James Monroe  b. 1904, d. 1954
Mason
Maysville
Gault, Edward  b. 1772, d. 1818
Lewis, Bridgett Lovelace  b. 1777, d. 1847
Old Washington
Calhoun, Lois E  b. 1921, d. 2019
Shannon
Gault, Edward L  b. 1804, d. 1885
Mason County
Bragg, Elizabeth  b. 1782, d. 1832
Gault, Edward  b. 1772, d. 1818
Gault, Edward L  b. 1804, d. 1885
Gault, Robert  b. 1858
Lewis, Bridgett Lovelace  b. 1777, d. 1847
Lewis, Charles Nelms  b. 1773, d. 1813 or 1814
Ringo, Adaline  b. 1816, d. 1892
McCracken
West Paducah
Curtis, Arthur S  b. 1907, d. 2002
McCreary County
Hogg, Nora  b. 1894, d. 1971
Menifee
Adams, Carma S  b. 1905, d. 1976
Civil District 2
Adams, Andrew Sherman  b. 1865, d. 1939
Adams, Carma S  b. 1905, d. 1976
Adams, Dorothy Inez  b. circa 1911, d. 1942
Adams, Rosa E  b. 1900, d. 1988
Adams, Vada Ethel  b. 1908, d. 1992
Back, Charles F  b. circa 1909
Back, Clara  b. 1903, d. 1991
Back, Clyde C  b. 1901, d. 1990
Back, Corbett  b. 1907, d. 1983
Back, Herbert Clay  b. 1907, d. 1970
Back, James Franklin  b. 1875, d. 1961
Back, Jesse Willard  b. 1918, d. 1998
Back, Joseph Woodford  b. 1873, d. 1965
Back, Lionel Ernest  b. 1910, d. 2001
Back, Nettie  b. 1902, d. 1997
Back, Raymond Earl  b. 1908, d. 1983
Back, Verona  b. 1905, d. 1998
Back, Wilgus M  b. 1917, d. 1988
Bair, James  b. circa 1898
Craft, Canzalia  b. circa 1874, d. 1959
Craft, Phoebe Jane  b. 1869, d. 1945
Hogg, Flora  b. 1879, d. 1973
Frenchburg
Craft, Martha  b. 1875, d. 1963
Fugate, Jesse Browning  b. 1871, d. 1960
Fugate, Laodecea  b. 1859, d. 1946
Fugate, Nancy A  b. 1857, d. 1938
Long, Christopher Columbus  b. 1867, d. 1942
Long, Simon DeLafayette  b. 1870, d. 1941
Lyons, Greene Riley  b. 1886, d. 1965
Magisterial District 2
Back, James Franklin  b. 1875, d. 1961
Craft, Canzalia  b. circa 1874, d. 1959
Pomeroyton
Rose, Ella Jane  b. 1870, d. 1941
Wellington
Adams, Rosa E  b. 1900, d. 1988
Back, Analisa  b. 1858, d. 1944
Back, Jesse Willard  b. 1918, d. 1998
Craft, Nevada  b. 1872, d. 1959
Fugate, Claude  b. 1903, d. 1913
Fugate, Ira S  b. 1871, d. 1926
Fugate, James Nathan  b. 1897, d. 1977
Fugate, Mary F  b. 1893
Hogg, Bryan  b. 1895, d. 1937
Hogg, Esther  b. 1921, d. 1994
Hogg, Hiram D  b. 1853, d. 1926
Hogg, Mary Myrtle  b. 1916, d. 1998
Hogg, Redwine W  b. 1893, d. 1962
Hogg, Stanley E  b. 1920, d. 1985
Hogg, Thelma  b. 1918, d. 1981
Shepard, Bertha  b. 1897, d. 1964
Menifee County
Adams, No Named  b. 1913
Menifee County
Adams, America Ann  b. 1894, d. 1961
Adams, Andrew Sherman  b. 1865, d. 1939
Adams, Bruce L  b. 1893, d. 1979
Adams, Dorsey Franklin  b. 1891, d. 1980
Back, Analisa  b. 1858, d. 1944
Back, Herbert Clay  b. 1907, d. 1970
Back, James Franklin  b. 1875, d. 1961
Back, Jesse Willard  b. 1918, d. 1998
Back, Joseph Woodford  b. 1873, d. 1965
Back, Lionel Ernest  b. 1910, d. 2001
Back, Nancy  b. 1840, d. 1923
Back, Raymond Earl  b. 1908, d. 1983
Back, Wilgus M  b. 1917, d. 1988
Bolin, Coma Festus  b. 1899, d. 1983
Calhoun, Clayton  b. 1878, d. 1950
Calhoun, John Miles  b. circa 1858
Carpenter, America Ellen  b. 1869, d. 1948
Carpenter, Henry C  b. 1874, d. 1921
Carpenter, Jacob Sandusky  b. 1885, d. 1966
Carpenter, Lillie  b. 1878, d. 1948
Carpenter, Mary Belle  b. 1876, d. before 1932
Carpenter, Milburn  b. 1883, d. 1969
Carpenter, Sarah Jane  b. 1870, d. 1944
Collinsworth, Flora  b. 1896, d. 1976
Craft, Aaron Wilson  b. 1886, d. 1969
Craft, America  b. 1862, d. 1896
Craft, Benjamin Franklin  b. 1864, d. 1925
Craft, Canzalia  b. circa 1874, d. 1959
Craft, John Linville  b. 1832, d. 1905
Craft, Lettie  b. 1866, d. 1951
Craft, Martha  b. 1875, d. 1963
Craft, Mary Evoline  b. 1859, d. 1924
Craft, Nannie G  b. 1897, d. 1983
Craft, Phoebe Jane  b. 1869, d. 1945
Craft, Willard Ernest  b. 1907, d. 1978
Fugate, Claude  b. 1903, d. 1913
Fugate, Jessie Lee  b. 1912, d. 1984
Fugate, Nancy A  b. 1857, d. 1938
Fugate, Nathan  b. 1852, d. 1924
Hall, Agustus
Hogg, Alexander Hargis  b. 1888, d. 1963
Hogg, Bryan  b. 1895, d. 1937
Hogg, Flora  b. 1879, d. 1973
Hogg, Hiram D  b. 1853, d. 1926
Hogg, Lucy  b. 1882, d. 1935
Keith, Ledford  b. 1894, d. 1974
Lawson, Andrew
Long, Christopher Columbus  b. 1867, d. 1942
Lyons, Ada  b. 1885, d. 1935
Lyons, George Maxey  b. 1863, d. 1919
Mann, Rhoda  b. 1866, d. 1945
Morefield, Daniel B  b. 1854, d. 1923
Morefield, Evaline  b. 1853, d. 1942
Morefield, William  b. 1874
Wells, Charles F  b. 1869, d. 1942
Williams, Hiram  b. 1853, d. 1904
Mercer
Harrodsburg
Curry, Helen M  b. 1918, d. 1980
Montgomery
Jeffersonville
Craft, Nannie G  b. 1897, d. 1983
Craft, Willard Ernest  b. 1907, d. 1978
Mounht Sterling
Lee, Daniel Boone  b. 1902, d. 1957
Mount Sterling
Vest, George Ann  b. 1895, d. 1981
Mt Sterling
Bolin, Coma Festus  b. 1899, d. 1983
Combs, Richard  b. 1820, d. 1887
Montgomery County
Adams, Carma S  b. 1905, d. 1976
Adams, Dorsey Franklin  b. 1891, d. 1980
Calhoun, Harlan D  b. 1878, d. 1968
Calhoun, Luther Kash  b. 1887, d. 1954
Duff, Okie Mae  b. 1910, d. 1990
Fugate, Laodecea  b. 1859, d. 1946
Hogg, Alexander Hargis  b. 1888, d. 1963
Morgan
Bonny
Pieratt, Elizabeth Ann  b. 1898, d. 1980
Cannel City
Rose, Annie  b. 1869, d. 1951
Chapel
Browning, Mary Jane  b. 1835, d. 1922
Fugate, Nathan Ellington  b. 1831, d. 1908
Fugate, William P  b. 1878
District 2
Craft, Saphrona B  b. 1893, d. 1969
Fannin, Thomas Morton  b. 1890, d. 1958
Division 2
Back, Hiram  b. 1831, d. 1861
Back, James Sanford  b. 1855, d. 1939
Back, Margaret  b. 1853
Back, Permelia Francis  b. 1859
Back, Sarah Ann  b. 1857, d. 1918
Hogg, Nancy  b. 1837, d. 1919
Ezel
Craft, Saphrona B  b. 1893, d. 1969
Fannin, Thomas Morton  b. 1890, d. 1958
Grassy Creek
Fugate, Nathan Ellington  b. 1831, d. 1908
Fugate, Nevada Drusilla  b. 1867, d. 1948
Licking River
Fugate, Sarah Elizabeth  b. 1854, d. 1926
Wells, Melvin  b. 1829, d. 1895
Magisterial District 2
Adams, America Ann  b. 1894, d. 1961
Adams, Andrew Sherman  b. 1865, d. 1939
Adams, Arthur Monroe  b. 1896, d. 1964
Adams, Bruce L  b. 1893, d. 1979
Adams, Dorsey Franklin  b. 1891, d. 1980
Adams, Nancy J  b. 1898, d. 1974
Craft, Phoebe Jane  b. 1869, d. 1945
Mize
Fugate, Jesse Browning  b. 1871, d. 1960
West Liberty
Adams, James Wealth  b. 1842, d. 1934
Collins, Eula  b. 1847, d. 1936
Fugate, Sarah Elizabeth  b. 1854, d. 1926
Tutt, Rosaline  b. 1870, d. 1953
Morgan County
Adams, Arthur Monroe  b. 1896, d. 1964
Adams, Stephen  b. 1780, d. 1858
Allen, Mahala  b. 1850, d. 1929
Back, Analisa  b. 1858, d. 1944
Back, Calvin  b. 1866, d. 1943
Back, James Sanford  b. 1855, d. 1939
Back, Permelia Francis  b. 1859
Back, Raymond Earl  b. 1908, d. 1983
Back, Sarah Ann  b. 1857, d. 1918
Brown, Coleman  b. 1845, d. 1923
Browning, Mary Jane  b. 1835, d. 1922
Craft, Alexander  b. 1867, d. 1901
Craft, Benjamin Franklin  b. 1864, d. 1925
Craft, Cora M  b. 1888, d. 1979
Craft, George Lee  b. 1892, d. 1965
Craft, Henry Clarence  b. 1900, d. 1971
Craft, Martha  b. 1875, d. 1963
Craft, Mary Evoline  b. 1859, d. 1924
Craft, Saphrona B  b. 1893, d. 1969
Craft, Sarah J  b. 1868, d. 1953
Dillon, Martha
Dunn, Floyd Carroll  b. 1908, d. 1991
Fannin, Thomas Morton  b. 1890, d. 1958
Frazier, Sarah  b. 1810, d. 1900
Fugate, Ira S  b. 1871, d. 1926
Fugate, Jesse Browning  b. 1871, d. 1960
Fugate, Laodecea  b. 1859, d. 1946
Fugate, Nancy A  b. 1857, d. 1938
Fugate, Nathan  b. 1852, d. 1924
Fugate, Nathan Ellington  b. 1831, d. 1908
Fugate, Nevada Drusilla  b. 1867, d. 1948
Fugate, Noviah W  b. 1874
Fugate, Sarah Elizabeth  b. 1854, d. 1926
Fugate, Unknown  b. 1855
Fugate, Zachariah  b. 1810, d. 1900
Hogg, Alexander Hargis  b. 1888, d. 1963
Hogg, Flora  b. 1879, d. 1973
Hogg, Mathilda  b. 1808, d. 1878
Hogg, Polly Ann  b. 1845, d. 1917
Lacey, Rachel  b. 1831, d. 1903
Lawson, Bruce (Rev)  b. 1882, d. 1967
Long, Christopher Columbus  b. 1867, d. 1942
Long, Simon DeLafayette  b. 1870, d. 1941
Mann, Rhoda  b. 1866, d. 1945
Morefield, Daniel B  b. 1854, d. 1923
Polly, Sally  b. circa 1784, d. 1850
Rose, Annie  b. 1869, d. 1951
Rose, David B  b. 1829, d. 1902
Stamper, Amelia Caroline  b. 1833, d. 1927
Stamper, Denny C  b. 1899, d. 1975
Stamper, James H  b. 1846, d. 1907
Stamper, Laodica  b. 1829, d. 1891
Stamper, Lucinda Jane  b. 1838, d. 1922
Stamper, Thomas Franklin  b. 1858, d. 1938
Stamper, William  b. 1774, d. 1852
Stamper, William Letcher  b. 1856, d. 1920
Stamper, William M  b. 1831, d. 1868
Vest, George Ann  b. 1895, d. 1981
Wells, Melvin  b. 1829, d. 1895
Wells, Sanford D  b. 1862, d. 1929
Williams, Jeptha  b. 1834, d. before 1880
Nelson
Bardstown
Adams, Martha  b. 1876, d. 1962
New Haven
Calhoun, Mae  b. 1906, d. 1996
Calhoun, Robert  b. 1873, d. 1948
Nelson County
Calhoun, Joseph J  b. 1913, d. 1969
Calhoun, Kelly  b. 1920, d. 1964
Calhoun, Lee Clay  b. 1902, d. 1962
Calhoun, Mae  b. 1906, d. 1996
Combs, Stephen  b. 1871, d. 1943
Ohio
Olaton
Webb, Viola  b. 1906
Owsley
Booneville
Combs, Sarah Ann  b. 1842, d. 1888
Duff, Elijah C  b. 1835, d. 1927
Eversole, Polly  b. 1839, d. 1909
Hogg, Alice  b. circa 1871, d. 1941
Hogg, Alice Louise  b. 1905, d. 1912
Hogg, Belle  b. circa 1866
Hogg, Charles  b. 1866, d. 1933
Hogg, Edward E  b. 1862, d. 1922
Hogg, Emma C  b. 1903, d. 1919
Hogg, George Madison  b. 1868, d. 1923
Hogg, George Madison Jr  b. 1919, d. 1981
Hogg, Harold E  b. 1915, d. 1981
Hogg, Henry B  b. circa 1864
Hogg, Henry C  b. circa 1868
Hogg, Hiram  b. 1800, d. 1863
Hogg, Hiram  b. 1833, d. 1916
Hogg, Ida G  b. 1873, d. 1956
Hogg, Jacob Snyder  b. 1908, d. 1962
Hogg, Katerine Grey  b. 1876, d. 1933
Hogg, Laura  b. circa 1868, d. 1924
Hogg, Laura Pearl  b. 1884
Hogg, Lucilla  b. circa 1902
Hogg, Martha J  b. 1863, d. 1922
Hogg, Mary  b. 1853, d. 1892
Hogg, Norman Hanson  b. 1917, d. 2005
Hogg, Robert Letcher  b. 1873, d. 1956
Hogg, Samuel Tilden  b. 1876, d. 1943
Hogg, Stephen Polly  b. 1831, d. 1917
Hogg, William P  b. 1878, d. 1918
Minter, Mae  b. 1892, d. 1913
Minter, Thomas C  b. 1884, d. 1945
Seale, Joseph Elmer  b. 1893, d. 1938
Sebastian, James G  b. 1867, d. 1944
Snyder, Virginia  b. 1845
Williams, Sarah  b. circa 1775, d. 1869
Wilson, Martha  b. 1879, d. 1950